Ergebnisse 1 - 91 von 91
Tabelle mit gestreifen Reihen.
Sortiert nach in Bezug auf Maine
Sorieren nach Zahl
USA, Sozialversicherungsindex, 1936-2007 (auf Englisch)133.418.498
Patent- und Markenamt der USA, US-Patente, 1970-2019 (auf Englisch)29.108.340
USA, Steuerveranlagungslisten der Bundessteuerbehörde, 1862-1918 (auf Englisch)8.850.878
U.S. County Land Ownership Maps, 1860-1918 (with Owner Name Index) (auf Englisch)6.940.589
USA, Patente des Patent- und Markenbüros, 1790-1909 (auf Englisch)3.577.054
USA, Freedmen's Bureau Records, 1865-1878 (auf Englisch)3.235.082
Ernennung von US-Postamtvorstehern, 1832-1971 (auf Englisch)1.514.110
USA, vom Büro indianischer Angelegenheiten erhaltene Briefe, 1824-1881 (auf Englisch)907.100
USA, Freedman's Bank Records, 1865-1874 (auf Englisch)685.322
Maine, USA, Landkreis York, Nachlassdateien, 1690-1917 (auf Englisch)508.689
U.S., Union Provost Marshal Files of Individual Civilians, 1861-1866 (auf Englisch)502.957
USA, Themenindex zu Korrespondenz- und Falldateien des Einwanderungs- und Einbürgerungsdiensts (INS), 1903-1959 (auf Englisch)410.831
Maine, USA, Testamente und Nachlassaufzeichnungen, 1584-1999 (auf Englisch)370.420
USA, endgültige Rechenschaftslisten von Evakuierten in Umsiedlungszentren, 1944-1946 (auf Englisch)149.092
U.S., Union Provost Marshal Files of Two or More Civilians, 1861-1866 (auf Englisch)107.471
Bewerbungsdateien für Kriegspensionen und Gutschriften von Grundstücken nach dem Unabhängigkeitskrieg, 1800-1900 (auf Englisch)83.050
USA, Aufzeichnungen zur Einberufung von Mitgliedern des Stammes der östlichen Cherokee durch Guion Miller, 1908-1910 (auf Englisch)79.496
USA, Zuweisungen von Land in Kriegszeiten, 1789-1858 (auf Englisch)76.126
Maine, USA, Landkreis Piscataquis, Urkundenbücher, 1838-1902 (auf Englisch)56.970
Gerichtsdaten aus Maine, 1696-1854 (auf Englisch)55.254
USA, House of Representative Private Claims, Vol. 1 (auf Englisch)22.958
USA, House of Representative Private Claims, Vol. 3 (auf Englisch)20.768
Abraham Lincoln-Papiere (auf Englisch)20.158
USA, FBI-Dateien zur Identifizierung verstorbener Krimineller, 1971-1994 (auf Englisch)19.807
Mayflower, Urkunden und Testamente, 1600-1850 (auf Englisch)18.601
USA, House of Representative Private Claims, Vol. 2 (auf Englisch)18.363
USA, ratifizierte indianische Abkommen,1722-1869 (auf Englisch)10.048
U.S.A.: Jüdische Namen in ausgewählten Dateien des Staatsdepartements, 1910-1929 (auf Englisch)9.724
US- und Weltatlanten, 1822-1923 (auf Englisch)8.170
USA, definitive Liste von Sklaven und Eigentum, 1827-1828 (auf Englisch)4.931
Irland, irische Auswanderungslisten, 1833-1839 (auf Englisch)3.421
US-Departement des Innern, Entscheidungen über Pensionen und Landansprucherhebungen, 1886-1930 (auf Englisch)3.310
Maine, USA, Landzuteilungen im amerikanischen Bürgerkrieg, 1776-1780 (auf Englisch)2.679
Native Soil Manuscripts Index (auf Englisch)2.356
USA, Identifikationskartendateien von Agenten der Prohibition, 1920-1925 (auf Englisch)1.772
Maine, USA, Bewerbungen für Grundstücke im Amerikanischen Bürgerkrieg, 1835-1836 (auf Englisch)1.483
Minutes of the court of Albany, Rensselaerswyck and Schenectady (auf Englisch)1.474
English Origins of New England Families, Second Series Vol. II (auf Englisch)1.046
English Origins of New England Families, Second Series Vol. III (auf Englisch)997
Maine Wills, 1640-1760 (auf Englisch)962
English Origins of New England Families, Vol. III (auf Englisch)883
English Origins of New England Families, Vol. II (auf Englisch)845
Minutes of the court of Fort Orange and Beverwyck (auf Englisch)652
Alleged frauds against certain Indian soldiers (auf Englisch)590
The Mayflower Reader (auf Englisch)530
History of York, Maine, Vol. I (auf Englisch)476
Lincoln County, Maine, Probate Records, 1760-1800 (auf Englisch)453
History of York, Maine, Vol. II (auf Englisch)433
The Tichborne romance (auf Englisch)429
American Wills and Administrations (auf Englisch)423
Record of Indentures [1771-1773] (auf Englisch)362
The Maine register and business directory for the year 1856 (auf Englisch)360
Family record of the Henderson and Whiddon families and their descendants (auf Englisch)316
English Origins of American Colonists (auf Englisch)294
The government of Maine : its history and administration (auf Englisch)279
The Pioneers of Maine and New Hampshire, 1623-1660 (auf Englisch)259
Fifty Puritan ancestors, 1628-1660 : genealogical notes, 1560-1900 (auf Englisch)230
Collections for a genealogy of the noble families of Henzey, Tyttery, and Tyzack (De Hennezel, De Thiétry, and Du Thisac) (auf Englisch)218
USA, Album von Kriminellen, 1906 (auf Englisch)203
Records of the Halls of Wallingford and the Buckinghams of Milford (auf Englisch)166
La familia de Sor Juana Ines de la Cruz : documentos inéditos (auf Englisch)158
The Unton inventories, relating to Wadley and Faringdon, Co. Berks., in the years 1596 and 1620 (auf Englisch)142
A Calendar of the White Collection of Manuscripts in the Public Archives of Nova Scotia (auf Englisch)140
English Estates of American Settlers (auf Englisch)109
Carter (auf Englisch)109
Calendar of "Parsons" wills and administrations (Prerogative Court of Canterbury, &c., Somerset House, London) : from A.D. 1417 (auf Englisch)109
Early wills illustrating the ancestry of Harriot Coffin : with genealogical and biographical notes (auf Englisch)90
Family data relating to Fouts, Yount, Taylor & Hoovers (auf Englisch)87
To the descendants of Timothy Ingraham : information respecting the great Ingraham estate in the kingdom of Great Britain (auf Englisch)81
The Records of the Cranston family (auf Englisch)74
Land titles in old Pittston (auf Englisch)56
Division of Abington: closing argument of Hon. Ellis W. Morton before the Committee of the Legislature on Towns (auf Englisch)50
Early town records of Newcastle, Maine, from June 24, 1756, to January 6, 1779 (auf Englisch)49
Abstracts of the wills of the Mather family (auf Englisch)39
Addenda to items of ancestry (auf Englisch)38
Dew wills and administrations : in the Prerogative Court of Canterbury (auf Englisch)37
Edward Washington and his kin (auf Englisch)37
1902 Kingfield register (auf Englisch)34
Report of the executive board of the Friends' Association of Philadelphia and Its Vicinity, for the Relief of Colored Freedmen (auf Englisch)32
Extracts from British archives on the families of Halley, Hawley, Pyke, etc. (auf Englisch)32
A pedigree & genealogical notes, from wills, registers, and deeds of the highly distinguished family of Penn. (auf Englisch)29
USA, Korrespondenz der American Protective League, 1917-1919 (auf Englisch)24
Will of Samuel St. John, 1844 (auf Englisch)23
Copies of public records re William Huddleston land grant (auf Englisch)20
Forbes family information (auf Englisch)20
Facts about the Carroll County Kearsarge Mountain of New Hampshire (auf Englisch)18
Halleian miscellany. (auf Englisch)16
Abstracts of wills and administration papers (auf Englisch)15
Botts family data (auf Englisch)13
This plan of Kennebeck & Sagadahock Rivers & country adjacent (auf Englisch)7
A centennial law suit (auf Englisch)3

Zu allen für Maine eindeutigen Sammlungen umwechseln